PRUDENCE CREOLE
 
UNITÉ LÉGALE
Dénomination SocialePRUDENCE CREOLE
Siège Social32 RUE ALEXIS DE VILLENEUVE
97400 SAINT-DENIS
Forme JuridiqueSA à conseil d'administration (s.a.i.)
Immatriculation1/1/1972
N° SIREN310863139
Capital7026960 EUR
Code NAF65.12Z (NAFRev2)
ActivitéAutres assurances
Effectif salarié100 à 199
TVA IntracommunautaireFR1310863139
HISTORIQUE
7/1/2019Changement de catégorie → économie non sociale
1/1/2008Changement d'activité → 65.12Z (NAFRev2)
12/25/1993Changement d'activité → 66.0E (NAF1993)
1/1/1993Changement de dénomination sociale → PRUDENCE CREOLE
1/1/1990Changement de dénomination sociale → PRUDENCE-CREOLE-GFA
1/1/1972Création → LA CREOLE SA à conseil d'administration (s.a.i.)
OBSERVATIONS
19/08/2016 Fusion - L236-1 à compter du 01/08/2016 :Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération :PRUDENCE CREOLE, Société anonyme (SA), 32 rue Alexis de Villeneuve - BP 301 97466 ST DENIS (RCS ST DENIS DE LA REUNION TGI (9741) 310 863 139), Société absorbanteBOURBON COURTAGE, Société par actions simplifiée (SAS), 32 rue Alexis de Villeneuve 97400 ST DENIS (RCS ST DENIS DE LA REUNION TGI (9741) 399 936 996), Société absorbée
06/08/2021 Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : société civile - SAINT - MARC 32 Rue Alexis De Villeneuve BP 301 97466 SAINT-DENIS, 484 836 036 RCS GTC Mixte de St Denis de La Réunion, société apporteuse avec date d'effet au 04/12/2020
23/05/2022 FUSION- ABSORPTION DE LA SOCIETE CONCORDE REUNION
28/12/2017 La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 40 200 000.00 FRF nouveau montant : 6 128 450.49 Eur
REPRÉSENTANTS
typeDirecteur général déléguéCorine, Solange, Christine BELLOC
né(e) en 09/1965
Nationalité FRANÇAISE
97417 Saint-Denis
FRANCE
typeDirecteur GénéralJean-benoît, Marie, Christophe, Joseph BORDES
né(e) en 11/1968
Nationalité FRANÇAISE
97417 Saint-Denis
FRANCE
typeAdministrateurElise, Claire GINIOUX
né(e) en 01/1980
Nationalité FRANÇAISE
75017 Paris 17e Arrondissement
FRANCE
typeAdministrateurGENERALI IARD
2 Rue Pillet Will
75009 PARIS 9E ARRONDISSEMENT
typeAdministrateurGENERALI FRANCE
2 Rue Pillet Will
75009 PARIS 9E ARRONDISSEMENT
typeCommissaire aux comptes titulaireKPMG S.A
Tour Eqho 2 Avenue Gambetta
Paris la Defense 92066
92400 COURBEVOIE
typePrésident du conseil d’administrationRégis LEMARCHAND
né(e) en 01/1970
Nationalité FRANÇAISE
93200 Saint-Denis
FRANCE
BÉNÉFICIAIRES
typeL'Accès au registre des bénéficiaires effectifs est désormais réservé aux professions listées à l'article L.561-2 du CMF.
Si vous êtes avocat, notaire, huissier, comptable, journaliste, vous pouvez demander un accès via ce formulaire.
Si vous disposez déjà d'un code d'accès, veuillez le renseigner ici :
ACTES - (67 actes dans 51 dépôts)
pdfLettre
Modification relative aux dirigeants d'une société
pdfProcès-verbal d'assemblée générale
Modification relative aux dirigeants d'une société
pdfProcès-verbal d'assemblée générale
Modification relative aux dirigeants d'une société
pdfProcès-verbal d'assemblée générale
Modification relative aux dirigeants d'une société
pdfProcès-verbal d'assemblée générale
Modification relative aux dirigeants d'une société
pdfProcès-verbal d'assemblée générale
Modification relative aux dirigeants d'une société

Extrait de procès-verbal du conseil d'administration
Modification relative aux dirigeants d'une société
pdfProcès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
fusion absorption
pdfTraité de fusion
fusion absorption
pdfProcès-verbal d'assemblée générale
Modification relative aux dirigeants d'une société
pdfStatuts mis à jour
Mise en harmonie des statuts
pdfAC 9741 1972B00059 2017 02124
pdfAC 9741 1972B00059 2017 01554
pdfAC 9741 1972B00059 2016 03784
pdfAC 9741 1972B00059 2016 03785
pdfAC 9741 1972B00059 2016 02727
pdfAC 9741 1972B00059 2016 01765
pdfAC 9741 1972B00059 2016 00469
pdfAC 9741 1972B00059 2015 04800
pdfAC 9741 1972B00059 2015 02769
pdfExtrait de procès-verbal du conseil d'administration

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
pdfAC 9741 1972B00059 2014 01788
pdfProcès-verbal d'assemblée générale ordinaire
pdfProcès-verbal d'assemblée
pdfAC 9741 1972B00059 2011 03795
pdfProcès-verbal d'assemblée
pdfAC 9741 1972B00059 2009 04061
pdfAC 9741 1991B00396 2009 04061
pdfProcès-verbal d'assemblée
pdfStatuts mis à jour
pdftUJu1whG57dP RACT0801310685
pdfProcès-verbal du conseil d'administration
pdfProcès-verbal d'assemblée

Procès-verbal du conseil d'administration
pdfProcès-verbal d'assemblée
pdfStatuts mis à jour
pdfProcès-verbal d'assemblée
pdfProcès-verbal d'assemblée

Procès-verbal du conseil d'administration
pdfProcès-verbal du conseil d'administration
Divers

Divers
Divers
pdfProcès-verbal du conseil d'administration
pdfProcès-verbal d'assemblée

Procès-verbal du conseil d'administration
pdfProcès-verbal d'assemblée
Divers

Statuts mis à jour
Divers

Divers
Divers
pdfhImEbZyvKPz0 RACT0100850012
pdfDivers
Divers
pdfDivers
Divers

Procès-verbal du conseil d'administration
Divers
pdfDivers
Divers Divers
pdfPGwp0TeqibIn RACT9700655032
pdfGuCxfAx7uisU RACT9700804046
pdfProcès-verbal d'assemblée
pdfW3mbFx8oTZdW RACT9600158235
pdfv4zC5ZaSW7LQ RACT9600022865
pdfZ8JSrhTgFLIY RACT9500165652
pdfStatuts mis à jour

Déclaration de conformité

Procès-verbal du conseil d'administration

Procès-verbal d'assemblée
pdfProcès-verbal d'assemblée
pdf2024-06 - GIard - Lettre designation RP PC
pdf2024-06 - GF - Lettre designation RP PC
pdfEXTRAIT CA 2025 02 13 - PV PRUDENCE CREOLE - compo CA
COMPTES
Clôture
31/12/2022
Dépôt
26/06/2023
Clôture
31/12/2021
Dépôt
23/05/2022
Clôture
31/12/2020
Dépôt
30/12/2021
Clôture
31/12/2019
Dépôt
21/12/2020
Clôture
31/12/2018
Dépôt
11/10/2019
Clôture
31/12/2017
Dépôt
09/10/2018
Clôture
31/12/2016
Dépôt
04/07/2017
ETABLISSEMENTS
31086313900021
(siège)
65.12ZCréation
2/21/1990
 32 RUE ALEXIS DE VILLENEUVE
97400 SAINT-DENIS
PRUDENCE CREOLE
31086313900294
(secondaire)
65.12ZCréation
7/1/2021
 5 RUE GEORGES POMPIDOU
97470 SAINT-BENOIT
31086313900286
(secondaire)
65.12ZCréation
8/8/2017
 3 RUE LECONTE DE LISLE
97480 SAINT-JOSEPH
PRUDENCE CREOLE
31086313900278
(secondaire)
65.12ZCréation
7/19/2016
 30 RUE DE NICE
97400 SAINT-DENIS
PRUDENCE CREOLE
31086313900260
(secondaire)
65.12ZCréation
7/1/2014
 245 RUE MARIUS ET ARY LEBLOND
97430 LE TAMPON
PRUDENCE CREOLE
31086313900237
(secondaire)
65.12ZCréation
9/1/2012
 300 RUE DU LYCEE
LOCAL 9000 HLM STATION
97440 SAINT-ANDRE
31086313900252
(secondaire)
65.12ZCréation
12/1/2011
 241 B RUE MARIUS ET ARY LEBLOND
LOCAL NO 6 1ER ETAGE
97430 LE TAMPON
PRUDENCE CREOLE
31086313900203
(secondaire)
65.12ZCréation
2/22/2011
 45 B RUE DU FOUR A CHAUX
LOT 2 ET 3 RESIDENCE JEAN ALBANY I
97410 SAINT-PIERRE
PRUDENCE CREOLE
31086313900195
(secondaire)
65.12ZCréation
2/15/2011
 128 B RUE LUC LORION
LOT 8 ESPACE BANK
97410 SAINT-PIERRE
31086313900120
(secondaire)
65.12ZCréation
1/1/2000
 13 ROUTE DES PREMIERS FRANCAIS
LOCAL D
97460 SAINT-PAUL
PRUDENCE CREOLE
31086313900054
(secondaire)
65.12ZCréation
7/1/1992
 AVENUE DU DOCTEUR RAYMOND VERGES
N 154 A
97450 SAINT-LOUIS
31086313900245
(secondaire)
65.12ZCréation
1/2/2013
Fermeture
12/31/2021
19 A RUE PATRICE LUMUMBA
ZAC RAVINE A MARQUET
97419 LA POSSESSION
PRUDENCE CREOLE
31086313900229
(secondaire)
65.12ZCréation
3/26/2011
Fermeture
10/1/2017
57 RUE DU GENERAL LAMBERT
97480 SAINT-JOSEPH
PRUDENCE CREOLE
31086313900211
(secondaire)
65.12ZCréation
2/8/2011
Fermeture
7/1/2014
238 RUE JULES BERTAUT
RES LES TERRASSES D'ANISSY BAT C LOT 2
97430 LE TAMPON
PRUDENCE CREOLE
31086313900179
(secondaire)
65.12ZCréation
2/19/2007
Fermeture
3/1/2013
69 RUE LECONTE DE LISLE
97419 LA POSSESSION
PRUDENCE CREOLE
31086313900187
(secondaire)
65.12ZCréation
7/1/2006
Fermeture
1/1/2013
CTRE MEDICAL ET CIAL DE L'YLANG
ZI
97600 MAMOUDZOU
PRUDENCE CREOLE
31086313900153
(secondaire)
65.12ZCréation
4/1/2005
Fermeture
2/18/2008
70 RUE AUGUSTIN ARCHAMBAUD
97410 SAINT-PIERRE
PRUDENCE CREOLE
31086313900146
(secondaire)
65.12ZCréation
3/31/2005
Fermeture
3/6/2011
150 RUE MARIUS ET ARY LEBLOND
97410 SAINT-PIERRE
PRUDENCE CREOLE
31086313900138
(secondaire)
65.12ZCréation
4/1/2004
Fermeture
3/26/2011
RUE DU GENERAL LAMBERT
N20 C
97480 SAINT-JOSEPH
31086313900112
(secondaire)
66.0ECréation
1/1/2000
Fermeture
12/31/2002
21 RUE JULIETTE DODU
97400 SAINT-DENIS
31086313900104
(secondaire)
65.12ZCréation
1/1/2000
Fermeture
9/1/2012
1136 AVENUE ILE DE FRANCE
IMM SIOU N-13
97440 SAINT-ANDRE
31086313900088
(secondaire)
66.0ECréation
1/1/2000
Fermeture
12/31/2000
11 B RUE SAINT-PHILIPPE
97450 SAINT-LOUIS
31086313900096
(secondaire)
66.0ECréation
1/1/2000
Fermeture
3/31/2005
87 RUE AUGUSTIN ARCHAMBAUD
97410 SAINT-PIERRE
31086313900161
(secondaire)
65.12ZCréation
1/20/1998
Fermeture
7/31/2012
AVENUE MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY
72 B ET C
97490 SAINT-DENIS
31086313900070
(secondaire)
66.0ECréation
8/11/1994
Fermeture
3/31/2005
31 RUE MARIUS ET ARY LEBLOND
97410 SAINT-PIERRE
31086313900062
(secondaire)
66.0ECréation
4/1/1993
Fermeture
12/25/1998
56 AVENUE MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY
97490 SAINT-DENIS
PRUDENCE CREOLE
31086313900047
(secondaire)
66.0ECréation
1/1/1967
Fermeture
8/11/1994
50 RUE MARIUS ET ARY LEBLOND
97410 SAINT-PIERRE
31086313900039
(secondaire)
65.12ZCréation
1/1/1964
Fermeture
7/1/2021
AVENUE JEAN JAURES
A L'ANGLE
97470 SAINT-BENOIT
ACCORDS D'ENTREPRISES
31086313900021Signature
12/6/2024
Diffusion
2/24/2025
mobilité durableSystème de prime (autre qu'évolution)
31086313900021Signature
4/30/2024
Diffusion
6/24/2024
NAOEvolution des primes
Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
31086313900021Signature
2/9/2023
Diffusion
4/29/2024
avenant accord teletravailTélétravail
31086313900021Signature
3/2/2022
Diffusion
3/28/2022
accord NAO 2022
31086313900021Signature
3/16/2021
Diffusion
4/8/2021
NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
31086313900021Signature
10/8/2020
Diffusion
12/17/2020
accord sur le télétravail
31086313900021Signature
3/6/2020
Diffusion
5/18/2020
NAO 2020Egalité salariale F/H
Evolution des primes
Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
PERCO et PERCOI
31086313900021Signature
3/20/2019
Diffusion
5/28/2019
Prime exceptionnelle de pouvoir d'achatSystème de prime (autre qu'évolution)
31086313900021Signature
3/23/2018
Diffusion
6/5/2018
Accord NAO