BNP PARIBAS REAL ESTATE CONSEIL HABITATION & HOSPITALITY
 
UNITÉ LÉGALE
Dénomination SocialeBNP PARIBAS REAL ESTATE CONSEIL HABITATION & HOSPITALITY
Siège Social50 COURS DE L'ILE SEGUIN
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Forme JuridiqueSAS, société par actions simplifiée
Immatriculation12/20/1999
N° SIREN429167075
Code NAF68.31Z (NAFRev2)
ActivitéAgences immobilières
Effectif salarié20 à 49
TVA IntracommunautaireFR61429167075
HISTORIQUE
3/31/2025Fermeture ou mise en sommeil de la société
3/21/2022Transfert de siège → 429167075 00846
8/28/2018Changement de dénomination sociale → BNP PARIBAS REAL ESTATE CONSEIL HABITATION & HOSPITALITY
8/24/2018Changement de dénomination sociale → BNP PARIBAS REAL ESTATE CONSEIL - HABITATION & HOSPITALITY
7/31/2018Changement de dénomination sociale → BNP PARIBAS REAL ESTATE CONSEIL HABITATION & HOSPITALITY
3/1/2016Changement de catégorie → économie non sociale
1/24/2011Transfert de siège → 429167075 00572
9/26/2008Changement de dénomination sociale → BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL TRANSACTION & CONSEIL
1/1/2008Changement d'activité → 68.31Z (NAFRev2)
12/25/2004Changement d'activité → 70.3A (NAFRev1)
1/1/2004Transfert de siège → 429167075 00093
12/25/2003Changement de forme → SAS, société par actions simplifiée
1/1/2003Changement de dénomination sociale → ESPACES IMMOBILIERS
1/1/2001Changement de dénomination sociale → SINVIM MARKETING ET VENTES
12/25/1999Changement d'activité → 70.1F (NAF1993)
12/20/1999Création → SNC MEUNIER COMMERCIALISATION HABITAT Société en nom collectif
ACTES - (77 actes dans 33 dépôts)
pdfCHH - DAU 31 mars 2025
pdfTraite de fusion - CHH et Transaction 18022025 VD docx
pdfZRnG7YcmKM6k C0022A1001L456597D20240521H164956TPIJTES003PDBOR
pdfStatuts mis à jour

Décision(s) du président
Transfert du siège social
pdfExtrait de décision(s) de l'associé unique
Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant

Extrait de décision(s) de l'associé unique
Modification(s) statutaire(s)

Statuts mis à jour
pdfRapport du commissaire aux comptes

Statuts mis à jour

Décision(s) du président
Réduction du capital social
pdfDécision(s) de l'associé unique
du capital
pdfDécision(s) de l'associé unique
Apport partiel d'actif

Décision(s) de l'associé unique
Changement de la dénomination sociale

Décision(s) de l'associé unique
Changement de président

Décision(s) de l'associé unique
Modification(s) relative(s) aux organes de gestion, direction, administration ou contrôle

Statuts mis à jour

Déclaration de conformité
pdfProjet d'apport partiel d'actif
à la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL
pdfExtrait de décision(s) de l'associé unique
Changement relatif à l'objet social

Statuts mis à jour
pdfDécision(s) de l'associé unique
Changement de président
pdfDécision(s) de l'associé unique
Changement de président
pdfExtrait de procès-verbal
Refonte des statuts

Statuts mis à jour
pdfProcès-verbal
Reconstitution des capitaux propres
pdfExtrait de procès-verbal
Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant
pdfProcès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Changement de président

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Nomination de Directeurs Généraux Délégués

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Démission de directeur général

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Démission de vice-président
pdfStatuts mis à jour
Transfert du siège social d'un greffe extérieur

Décision(s) du président
Transfert du siège social

Liste des sièges sociaux antérieurs
pdfStatuts mis à jour
Transfert du siège social d'un greffe extérieur

Décision(s) du président
Transfert du siège social

Liste des sièges sociaux antérieurs
pdfStatuts mis à jour
Transfert du siège social d'un greffe extérieur

Décision(s) du président
Transfert du siège social

Liste des sièges sociaux antérieurs
pdfExtrait de procès-verbal
Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social
pdfActe
Reconstitution de l'actif net
pdfProcès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Adjonction d'un nom commercial

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Modification(s) statutaire(s)

Statuts mis à jour
pdfProcès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Adjonction d'un nom commercial

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Modification(s) statutaire(s)

Statuts mis à jour
pdfProcès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Adjonction d'un nom commercial

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Modification(s) statutaire(s)

Statuts mis à jour
pdfProcès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Changement de la dénomination sociale ESPACES IMMOBILIERS

Statuts mis à jour
pdfProcès-verbal d'assemblée générale mixte
Modification(s) statutaire(s)

Statuts mis à jour
pdfProcès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Nomination de directeur général
pdfProcès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Décision d'augmentation

Certificat
Attestation bancaire

Acte
Augmentation du capital social

Acte
Modification(s) statutaire(s)

Statuts mis à jour
pdfProcès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant
pdfProcès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Changement de président
pdfExtrait de procès-verbal
Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant
pdfProcès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social
pdfProcès-verbal d'assemblée générale mixte
Changement de la dénomination sociale

Statuts mis à jour
pdfProcès-verbal d'assemblée générale mixte
SAS

Procès-verbal d'assemblée générale mixte
Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

Procès-verbal d'assemblée générale mixte
Augmentation du capital social

Rapport du commissaire à la transformation

Statuts mis à jour
pdfProcès-verbal d'assemblée générale mixte
-

Statuts mis à jour
Divers
pdfProcès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
-

Statuts mis à jour
Divers
pdfStatuts constitutifs
Constitution
COMPTES
Clôture
31/12/2023
Dépôt
18/05/2024
Clôture
31/12/2022
Dépôt
14/06/2023
Clôture
31/12/2021
Dépôt
30/05/2022
Clôture
31/12/2020
Dépôt
31/05/2021
Clôture
31/12/2019
Dépôt
29/06/2020
Clôture
31/12/2018
Dépôt
31/05/2019
Clôture
31/12/2017
Dépôt
16/05/2018
Clôture
31/12/2016
Dépôt
09/05/2017
ETABLISSEMENTS
42916707500846
(siège)
68.31ZCréation
3/21/2022
Fermeture
3/31/2025
50 COURS DE L'ILE SEGUIN
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
42916707500820
(secondaire)
68.31ZCréation
1/1/2018
Fermeture
7/31/2018
122 AVENUE DE GRAMMONT
37000 TOURS
42916707500838
(secondaire)
68.31ZCréation
1/1/2018
Fermeture
7/31/2018
15 RUE DES CUIRASSIERS
IMMEUBLE SILEX 1
69003 LYON
42916707500796
(secondaire)
68.31ZCréation
9/1/2017
Fermeture
7/31/2018
1 ALLEE PIERRE DE FERMAT
1 A 5 IMMEUBLE VISION
63170 AUBIERE
42916707500812
(secondaire)
68.31ZCréation
5/15/2017
Fermeture
7/31/2018
9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
59800 LILLE
42916707500788
(secondaire)
68.31ZCréation
2/1/2017
Fermeture
7/31/2018
24 MAIL PABLO PICASSO
44000 NANTES
42916707500804
(secondaire)
68.31ZCréation
1/16/2017
Fermeture
7/31/2018
8 RUE DES TRENTE-SIX PONTS
8-10-IMMEUBLE ELIPSYS
31400 TOULOUSE
BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL TRANSACTION & C
42916707500770
(secondaire)
68.31ZCréation
7/1/2016
Fermeture
7/31/2018
1 AVENUE DOYEN LOUIS WEIL
1-5-EUROPOLE LE GRENAT
38000 GRENOBLE
42916707500762
(secondaire)
68.31ZCréation
3/1/2016
Fermeture
7/31/2018
IMMEUBLE LES PLEIADES
74330 EPAGNY METZ-TESSY
42916707500754
(secondaire)
68.31ZCréation
9/1/2015
Fermeture
7/31/2018
475 AVENUE DU PRADO
13008 MARSEILLE
42916707500739
(secondaire)
68.31ZCréation
3/1/2015
Fermeture
7/31/2018
37 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES
75008 PARIS
42916707500721
(secondaire)
68.31ZCréation
1/1/2015
Fermeture
7/31/2018
2 BOULEVARD VICTOR HUGO
06000 NICE
42916707500713
(secondaire)
68.31ZCréation
12/1/2014
Fermeture
11/2/2015
7 RUE SAINT-YVES
35000 RENNES
42916707500747
(secondaire)
68.31ZCréation
11/3/2014
Fermeture
7/31/2018
173 AVENUE DU GENERAL LECLERC
94700 MAISONS-ALFORT
42916707500697
(secondaire)
68.31ZCréation
4/22/2014
Fermeture
7/31/2018
36 RUE DES ETATS GENERAUX
78000 VERSAILLES
42916707500705
(secondaire)
68.31ZCréation
6/1/2013
Fermeture
7/31/2018
133 BOULEVARD SAINT-GERMAIN
75006 PARIS
42916707500689
(secondaire)
68.31ZCréation
2/1/2013
Fermeture
5/3/2017
2 RUE DU GENERAL LECLERC
59200 TOURCOING
42916707500663
(secondaire)
68.31ZCréation
8/1/2012
Fermeture
2/15/2017
58 RUE SAINT JEAN
54000 NANCY
42916707500655
(secondaire)
68.31ZCréation
4/1/2012
Fermeture
6/30/2014
40 COURS DU CHAPEAU ROUGE
33000 BORDEAUX
42916707500648
(secondaire)
68.31ZCréation
1/1/2012
Fermeture
4/22/2014
60 RUE DU MARECHAL FOCH
78000 VERSAILLES
42916707500622
(secondaire)
68.31ZCréation
1/1/2012
Fermeture
7/31/2018
64 RUE JEANNE D'ARC
76000 ROUEN
42916707500671
(secondaire)
68.31ZCréation
1/1/2012
Fermeture
7/31/2018
8 RUE CIMAROSA
75016 PARIS
42916707500580
(secondaire)
68.31ZCréation
8/23/2011
Fermeture
7/31/2018
6 COURS SEXTIUS
13100 AIX-EN-PROVENCE
42916707500630
(secondaire)
68.31ZCréation
7/1/2011
Fermeture
7/31/2018
2 PLACE RAVESIES
33000 BORDEAUX
42916707500572
(secondaire)
68.31ZCréation
1/24/2011
Fermeture
3/21/2022
167 QUAI DE LA BATAILLE DE STALINGRAD
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
42916707500564
(secondaire)
68.31ZCréation
1/1/2011
Fermeture
7/31/2018
40 RUE NOTRE-DAME DES VICTOIRES
75002 PARIS
42916707500598
(secondaire)
68.31ZCréation
11/2/2010
Fermeture
2/14/2018
129 RUE SERVIENT
69003 LYON
42916707500614
(secondaire)
68.31ZCréation
10/1/2010
Fermeture
9/7/2015
39 RUE SOMMEILLER
74000 ANNECY
42916707500523
(secondaire)
68.31ZCréation
9/1/2010
Fermeture
8/31/2011
1 RUE BERANGER
38000 GRENOBLE
42916707500481
(secondaire)
68.31ZCréation
9/1/2010
Fermeture
7/31/2018
100 BOULEVARD SADI CARNOT
06110 LE CANNET
42916707500556
(secondaire)
68.31ZCréation
9/1/2010
Fermeture
7/31/2018
39 RUE GRENETTE
39 A 41
69002 LYON
42916707500457
(secondaire)
68.31ZCréation
9/1/2010
Fermeture
3/11/2011
170 COURS DU MEDOC
33300 BORDEAUX
42916707500507
(secondaire)
68.31ZCréation
9/1/2010
Fermeture
7/31/2018
2 RUE DU DOME
67000 STRASBOURG
42916707500549
(secondaire)
68.31ZCréation
9/1/2010
Fermeture
12/15/2017
41 BOULEVARD DU MARECHAL FOCH
41-43
49100 ANGERS
42916707500416
(secondaire)
68.31ZCréation
9/1/2010
Fermeture
7/31/2018
8 CHEMIN DE LA TERRASSE
31500 TOULOUSE
42916707500531
(secondaire)
68.31ZCréation
9/1/2010
Fermeture
1/31/2017
8 RUE LA FAYETTE
44000 NANTES
42916707500432
(secondaire)
68.31ZCréation
9/1/2010
Fermeture
8/26/2011
12 PLACE DU MARECHAL FOCH
76000 ROUEN
42916707500515
(secondaire)
68.31ZCréation
9/1/2010
Fermeture
1/31/2016
319 AVENUE BERTHELOT
69008 LYON
42916707500408
(secondaire)
68.31ZCréation
9/1/2010
Fermeture
6/8/2017
1 PLACE OCCITANE
31000 TOULOUSE
42916707500499
(secondaire)
68.31ZCréation
9/1/2010
Fermeture
6/30/2014
5 PLACE MASSENA
06000 NICE
42916707500440
(secondaire)
68.31ZCréation
9/1/2010
Fermeture
3/11/2011
10 ALLEE DE TOURNY
33000 BORDEAUX
42916707500473
(secondaire)
68.31ZCréation
9/1/2010
Fermeture
1/31/2016
14 RUE DANIELLE CASANOVA
75002 PARIS
42916707500465
(secondaire)
68.31ZCréation
9/1/2010
Fermeture
3/31/2013
142 RUE DU BAC
75007 PARIS
42916707500424
(secondaire)
68.31ZCréation
9/1/2010
Fermeture
7/31/2018
10 RUE CARNOT
51100 REIMS
42916707500390
(secondaire)
68.31ZCréation
4/1/2010
Fermeture
2/21/2013
179 BOULEVARD DE TURIN
TOUR LILLE AXA EUROPE
59777 LILLE
42916707500606
(secondaire)
68.31ZCréation
2/19/2009
Fermeture
7/31/2018
455 PROMENADE DES ANGLAIS
IMMEUBLE LE PHOENIX
06000 NICE
42916707500374
(secondaire)
68.10ZCréation
1/1/2009
Fermeture
1/1/2010
168 AVENUE CHARLES DE GAULLE
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
42916707500366
(secondaire)
68.10ZCréation
1/1/2009
Fermeture
1/1/2010
3 PLACE PAUL VAILLANT COUTURIER
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
42916707500325
(secondaire)
68.10ZCréation
1/1/2009
Fermeture
11/3/2014
2 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
94160 SAINT-MANDE
42916707500341
(secondaire)
68.10ZCréation
1/1/2009
Fermeture
1/1/2010
53 RUE JEAN LONGUET
92290 CHATENAY-MALABRY
42916707500333
(secondaire)
68.31ZCréation
1/1/2009
Fermeture
7/31/2018
26 RUE DE VILLIERS
92300 LEVALLOIS-PERRET
42916707500382
(secondaire)
68.10ZCréation
1/1/2009
Fermeture
2/1/2013
9 B RUE AUGUSTE MOUNIE
92160 ANTONY
42916707500358
(secondaire)
68.10ZCréation
1/1/2009
Fermeture
1/1/2010
58 AVENUE JEAN JAURES
92150 SURESNES
42916707500317
(secondaire)
68.31ZCréation
1/1/2009
Fermeture
7/31/2018
1 RUE DE LA REPUBLIQUE
78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
42916707500309
(secondaire)
68.31ZCréation
1/1/2009
Fermeture
7/31/2018
6 RUE DE MAGUELONE
34000 MONTPELLIER
42916707500291
(secondaire)
68.31ZCréation
4/25/2008
Fermeture
7/31/2018
44 BOULEVARD DE DUNKERQUE
CS 11527
13002 MARSEILLE
42916707500283
(secondaire)
68.31ZCréation
9/15/2006
Fermeture
1/1/2009
10 RUE FRANCOIS COUPERIN
78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX
42916707500275
(secondaire)
68.31ZCréation
10/1/2005
Fermeture
12/31/2012
25 RUE DU CHAMP JACQUET
35000 RENNES
42916707500267
(secondaire)
68.31ZCréation
10/1/2005
Fermeture
12/4/2015
279 AVENUE DU PRADO
13008 MARSEILLE
42916707500259
(secondaire)
68.31ZCréation
9/1/2005
Fermeture
10/30/2010
1 RUE DE CLAMART
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
42916707500226
(secondaire)
68.31ZCréation
7/1/2005
Fermeture
4/1/2010
11 PARVIS DE ROTTERDAM
TOUR LILLE EUROPE
59777 LILLE
42916707500234
(secondaire)
68.31ZCréation
7/1/2005
Fermeture
6/30/2016
27 BOULEVARD GAMBETTA
38000 GRENOBLE
42916707500184
(secondaire)
68.31ZCréation
6/1/2005
Fermeture
4/30/2011
73 B RUE DU MAL FOCH
78000 VERSAILLES
42916707500218
(secondaire)
68.10ZCréation
5/2/2005
Fermeture
5/1/2011
13 B RUE LOUIS REVON
74000 ANNECY
42916707500192
(secondaire)
68.31ZCréation
5/2/2005
Fermeture
12/31/2010
6 PLACE DU PONT
95300 PONTOISE
42916707500176
(secondaire)
70.3ACréation
5/1/2005
Fermeture
10/1/2005
11 RUE LOUIS KERAUTRET-BOTMEL
35000 RENNES
42916707500242
(secondaire)
70.3ACréation
5/1/2005
Fermeture
4/17/2006
179 BOULEVARD RENE CASSIN
06200 NICE
42916707500150
(secondaire)
68.31ZCréation
2/1/2005
Fermeture
7/31/2010
36 RUE CHARLES RICHARD
69003 LYON
42916707500135
(secondaire)
68.31ZCréation
12/20/2004
Fermeture
10/1/2010
RUE EDMOND MICHELET
IMMEUBLE TOULOUSE LAUTREC
33000 BORDEAUX
42916707500168
(secondaire)
68.31ZCréation
10/15/2004
Fermeture
12/31/2014
PLACE VIARME
ZAC DU MARTRAY R PORTE NEU
44000 NANTES
42916707500101
(secondaire)
68.31ZCréation
10/15/2004
Fermeture
7/31/2010
3 AVENUE VICTOR HUGO
ET 3 R VILLARS
13100 AIX-EN-PROVENCE
42916707500119
(secondaire)
68.31ZCréation
10/15/2004
Fermeture
4/4/2013
62 RUE DE METZ
31000 TOULOUSE
42916707500200
(secondaire)
68.31ZCréation
10/13/2004
Fermeture
6/13/2010
17 RUE BOULARD
17-19
75014 PARIS
42916707500093
(secondaire)
68.31ZCréation
1/1/2004
Fermeture
1/24/2011
13 BOULEVARD DU FORT DE VAUX
75017 PARIS
42916707500127
(secondaire)
68.31ZCréation
1/3/2004
Fermeture
9/30/2010
6 RUE MACE
06400 CANNES
42916707500051
(secondaire)
68.10ZCréation
1/1/2004
Fermeture
11/4/2010
31 AVENUE DE LOWENDAL
75015 PARIS
42916707500044
(secondaire)
68.31ZCréation
1/1/2004
Fermeture
7/31/2018
196 RUE HOUDAN
92330 SCEAUX
42916707500069
(secondaire)
68.31ZCréation
1/1/2004
Fermeture
3/31/2010
31 RUE DE FRANCE
29 ET
06000 NICE
42916707500036
(secondaire)
68.31ZCréation
1/1/2004
Fermeture
10/31/2011
49 COURS VITTON
69006 LYON
42916707500077
(secondaire)
68.10ZCréation
1/1/2004
Fermeture
6/30/2012
7 PLACE DES TERNES
7-9
75017 PARIS
42916707500085
(secondaire)
68.10ZCréation
1/1/2004
Fermeture
7/21/2010
11 PLACE GAMBETTA
75020 PARIS
42916707500028
(secondaire)
70.1FCréation
10/2/2000
Fermeture
1/1/2004
38 AVENUE ARISTIDE BRIAND
92120 MONTROUGE
42916707500010
(secondaire)
70.1FCréation
12/20/1999
Fermeture
10/2/2000
235 AVENUE LE JOUR SE LEVE
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
42916707500143
(secondaire)
70.3ACréation
1/1/1900
Fermeture
12/25/2004
RUE BASSE PORTE
44000 NANTES