CIFFREO BONA
 
UNITÉ LÉGALE
Dénomination SocialeCIFFREO BONA
Siège Social211 AVENUE FRANCIS TONNER
211-213
06150 CANNES
Forme JuridiqueSAS, société par actions simplifiée
Immatriculation12/20/2005
N° SIREN487652257
Capital8199266 EUR
Code NAF46.73A (NAFRev2)
ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Effectif salarié250 à 499
TVA IntracommunautaireFR67487652257
HISTORIQUE
12/31/2020Changement d'activité → 46.73A (NAFRev2)
12/31/2018Changement d'activité → 46.73B (NAFRev2)
1/1/2008Changement de catégorie → économie non sociale
1/1/2008Changement d'activité → 46.73A (NAFRev2)
12/30/2006Changement d'activité → 51.5F (NAFRev1)
12/15/2006Changement de forme → SAS, société par actions simplifiée
6/30/2006Transfert de siège → 487652257 00022
12/20/2005Création → CIFFREO BONA Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
OBSERVATIONS
13/08/2008 Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination PROVENCE MATERIAUX Forme juridique SARL Siège social VALDEROURE (06750) 2840 Hameau la Ferrière Rcs Grasse B 385 345 962
01/01/2009 En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Brignoles ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Draguignan. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Draguignan décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
01/01/2009 En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Saint-Tropez ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Fréjus. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Fréjus décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
08/03/2012 Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination HERVE TAINTON MATERIAUX Forme juridique SARL Siège social ST CYR SUR MER (83270) Carrière du Tunnel Rcs B 343 329 454
REPRÉSENTANTS
typeCommissaire aux comptes titulaireDEREPAS SASSO ORGANISATION
455 Promenade DES ANGLAIS PORTE DE L'ARENAS
06200 Nice
typePrésident de SASETS CIFFREO ET BONA
2 Rue Diderot
06000 Nice
BÉNÉFICIAIRES
typeL'Accès au registre des bénéficiaires effectifs est désormais réservé aux professions listées à l'article L.561-2 du CMF.
Si vous êtes avocat, notaire, huissier, comptable, journaliste, vous pouvez demander un accès via ce formulaire.
Si vous disposez déjà d'un code d'accès, veuillez le renseigner ici :
ACTES - (46 actes dans 22 dépôts)
pdfZwwd1RYQIEjp C0022A1001L843254D20241014H163815TPIJTES003PDBOR
pdfProcès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
modification du mode d'administration

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Nomination de président

Statuts mis à jour
pdfProcès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Changement(s) de membre(s) du directoire
pdfProcès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Augmentation du capital social

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Modification(s) statutaire(s)

Projet de traité de fusion

Rapport du commissaire à la fusion

Statuts mis à jour
pdfProcès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Augmentation du capital social

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Modification(s) statutaire(s)

Projet de traité de fusion

Rapport du commissaire à la fusion

Statuts mis à jour
pdfProcès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Augmentation du capital social

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Modification(s) statutaire(s)

Projet de traité de fusion

Rapport du commissaire à la fusion

Statuts mis à jour
pdfProcès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Augmentation du capital social

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Modification(s) statutaire(s)

Projet de traité de fusion

Rapport du commissaire à la fusion

Statuts mis à jour
pdfProjet d'apport
fusion
pdfOrdonnance du président
Nomination de commissaire à la fusion
pdfProcès-verbal
Nomination(s) de membre(s) du directoire
pdfProcès-verbal
Démission(s) de membre(s) du directoire
pdfOrdonnance du président
Nomination de commissaire aux apports
pdfProcès-verbal
Changement(s) de membre(s) du directoire
pdfProcès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Nomination(s) de membre(s) du conseil de surveillance
pdfRapport du commissaire aux apports
pdfProcès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Fusion définitive

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
ARTICLE 6

Statuts mis à jour
pdfJ5yJSYUVWWvT RACT0800696202
pdfProjet de traité de fusion
PROJET DE FUSION PAR ABSORPTION DE LA SOCIETE PROVENCE MATERIAUX PAR LA SOCIETE CIFFREO BONA.
pdfProcès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Augmentation du capital social

Statuts mis à jour
pdfuV2cINHWUDMn RACT0700005036
pdfActe
SUR LES APPORTS RECUS A LA SARL PAR LA SAS CIFFREO BONA
pdfActe
SUR LA TRANSFORMATION DE LA STE EN SAS
pdfActe
PLACE SOUS LE REGIME DES SCISSIONS
pdfwp5Gy7huGehP RACT0601028608
pdfube6QrJosJJy RACT0600122378
COMPTES
Clôture
31/12/2023
Dépôt
19/09/2024
Clôture
31/12/2022
Dépôt
21/12/2023
Clôture
31/12/2021
Dépôt
24/10/2022
Clôture
31/12/2020
Dépôt
29/09/2021
BODACC
10/11/2024CANNESModifications diverses
9/22/2024CANNESDépôts des comptes
12/24/2023CANNESDépôts des comptes
11/23/2023DRAGUIGNANVentes et cessions
11/28/2023DRAGUIGNANVentes et cessions
10/26/2022CANNESDépôts des comptes
10/1/2021CANNESDépôts des comptes
12/11/2015CANNESModifications diverses
7/30/2013CANNESModifications diverses
2/19/2012CANNESModifications diverses
11/30/2011CANNESVentes et cessions
5/5/2011CANNESModifications diverses
11/27/2011TOULONVentes et cessions
12/26/2010CANNESModifications diverses
7/28/2010CANNESModifications diverses
7/27/2008CANNESModifications diverses
10/30/2008CANNESModifications diverses
ETABLISSEMENTS
CIFFREO BONA
48765225700022
(siège)
46.73ACréation
1/1/1900
 211 AVENUE FRANCIS TONNER
211-213
06150 CANNES
CIFFREO BONA
48765225700451
(secondaire)
46.73ACréation
11/2/2023
 34 ROUTE DEPARTEMENTALE N°225
LE VILLARD NORD
83830 CALLAS
48765225700444
(secondaire)
46.73ACréation
4/1/2022
 AVENUE DU PEYRAT
83310 GRIMAUD
CIFFREO BONA
48765225700436
(secondaire)
46.73ACréation
3/1/2021
 846 AVENUE DE DRAGUIGNAN
ZI TOULON EST
83130 LA GARDE
48765225700428
(secondaire)
46.73ACréation
2/1/2019
 LES ESCLAPES
83370 FREJUS
48765225700402
(secondaire)
46.73ACréation
7/2/2018
 AVENUE DES LIONS
ZAC DE POLE PRODUCTION NORD
83600 FREJUS
48765225700394
(secondaire)
46.73ACréation
5/1/2018
 BD DU RIVAGE
06150 CANNES
48765225700386
(secondaire)
46.73ACréation
4/14/2014
 132 AVENUE DE LA ROUBINE
06150 CANNES
CIFFREO BONA
48765225700378
(secondaire)
46.73ACréation
12/31/2011
 ROUTE DEPARTEMENTALE 559
CARRIERE DU TUNNEL RTE PORT D'ALON
83270 SAINT-CYR-SUR-MER
CIFFREO BONA
48765225700360
(secondaire)
46.73ACréation
12/31/2011
 LA BAOU
ZONE INDUSTRIELLE
83110 SANARY SUR MER
48765225700329
(secondaire)
46.73ACréation
12/22/2008
 SAINT JEAN
83170 BRIGNOLES
CIFFREO BONA
48765225700311
(secondaire)
46.73ACréation
4/30/2008
 2840 HAM LA FERRIERE
06750 VALDEROURE
48765225700295
(secondaire)
46.13ZCréation
3/3/2008
 ROUTE DEPARTEMENTALE DN7
83460 LES ARCS
CIFFREO BONA L'ENTREPOT PROFESSIONNEL
48765225700287
(secondaire)
46.73ACréation
10/1/2007
 151 VC ECHANGEUR DE JERUSALEM
CASTILLE
83210 LA FARLEDE
CIFFREO BONA - L'ENTREPOT DES PROS
48765225700261
(secondaire)
46.73ACréation
12/30/2006
 PARC ACTIVITES GRAND PONT
83310 GRIMAUD
CIFFREO BONA
48765225700063
(secondaire)
46.73ACréation
12/30/2006
 85 QUAI DES ARBOINS LE VILLAGE
554 QUAI ROUTE NATIONAL
06460 SAINT-VALLIER-DE-THIEY
CIFFREO BONA
48765225700089
(secondaire)
46.73ACréation
12/30/2006
 CHEMIN DE LA MADELEINE
ZONE INDUSTRIELLE DU CARRE
06130 GRASSE
CIFFREO BONA
48765225700113
(secondaire)
46.73ACréation
12/30/2006
 ZI SAINT HERMENTAIRE
RONE INDUSTRIELLE
83300 DRAGUIGNAN
CIFFREO BONA
48765225700139
(secondaire)
46.73ACréation
12/30/2006
 50 BOULEVARD JEAN MOULIN
LES GENETS
83700 SAINT-RAPHAEL
CIFFREO BONA
48765225700162
(secondaire)
46.73ACréation
12/30/2006
 QUARTIER LOMBARDIE
83440 TOURRETTES
CIFFREO BONA
48765225700188
(secondaire)
46.73ACréation
12/30/2006
 BOIS DU CHEMIN D AIX
83470 ST MAXIMIN LA STE BAUME
CIFFREO BONA - L'ENTREPOT DES PROS
48765225700196
(secondaire)
46.73BCréation
12/30/2006
 LES PLAYES
ZONE DES NEGADOUX ZAC
83140 SIX FOURS LES PLAGES
CIFFREO BONA
48765225700147
(secondaire)
46.73ACréation
12/30/2006
 ROUTE DEPARTEMENTALE N7
QUARTIER DE LA PALUD
83370 FREJUS
CIFFREO BONA
48765225700204
(secondaire)
46.73BCréation
12/30/2006
 ROUTE DEPARTEMENTALE 559
83240 CAVALAIRE-SUR-MER
CIFFREO BONA
48765225700238
(secondaire)
46.73ACréation
12/30/2006
 LA GRANDE BASTIDE
LIEUDIT
83980 LE LAVANDOU
CIFFREO BONA
48765225700071
(secondaire)
46.73ACréation
12/30/2006
 19 ROUTE DE DRAGUIGNAN
QUARTIER SAINT JACQUES
06130 GRASSE
CIFFREO BONA - L'ENTREPOT DES PROS
48765225700279
(secondaire)
46.73ACréation
12/30/2006
 VC ZI TOULON EST
83130 LA GARDE
CIFFREO BONA - L'ENTREPOT DES PROS
48765225700048
(secondaire)
46.73ACréation
12/30/2006
 CHEMIN DE CARIMAI
LIEUDIT LES FADES
06250 MOUGINS
CIFFREO BONA
48765225700030
(secondaire)
46.73ACréation
12/30/2006
 QRT L ABADIE
CANNES LA BOCCA LD L'ABADIE
06150 CANNES
CIFFREO BONA
48765225700253
(secondaire)
46.73BCréation
12/30/2006
 CAMP FERRAT
83120 SAINTE-MAXIME
CIFFREO BONA
48765225700105
(secondaire)
46.73ACréation
12/30/2006
 CHEMIN DE FONDURANE
83440 MONTAUROUX
CIFFREO BONA - L'ENTREPOT DES PROS
48765225700246
(secondaire)
46.73BCréation
12/30/2006
 LE BEAU VEZE
ZA ACTI SUD
83320 CARQUEIRANNE
CIFFREO BONA
48765225700055
(secondaire)
46.73ACréation
12/30/2006
 ROUTE DE DRAGUIGNAN
QUARTIER DU SUYE
06530 PEYMEINADE
SIGNATURE HOME CONCEPT
48765225700410
(secondaire)
46.73ACréation
10/1/2018
Fermeture
2/28/2021
VC ZI TOULON EST
83130 LA GARDE
48765225700345
(secondaire)
46.73ACréation
2/1/2009
Fermeture
4/1/2018
ZONE ARTISANALE ROUTE DE BRIGNOL
QUARTIER PRADERIES
83570 CARCES
48765225700352
(secondaire)
46.73ACréation
2/1/2009
Fermeture
2/1/2009
QUARTIER PRADERIES
ZONE ARTISANALE RTE DE BRIGNOLES
83570 CARCES
CIFFREO BONA L'ENTREPOT DES PROS
48765225700337
(secondaire)
46.73ACréation
12/1/2008
Fermeture
7/2/2018
LES BARESTES
83480 PUGET-SUR-ARGENS
48765225700303
(secondaire)
46.73ACréation
4/1/2008
Fermeture
4/1/2008
HAMEAU DE LA FERRIERE
06750 VALDEROURE
CIFFREO BONA
48765225700097
(secondaire)
46.73ACréation
12/30/2006
Fermeture
5/31/2010
ROUTE DE FREJUS
QUARTIER LE PLAN
83490 LE MUY
CIFFREO BONA
48765225700212
(secondaire)
46.73BCréation
12/30/2006
Fermeture
6/30/2012
LE PERAT
83310 GRIMAUD
CIFFREO BONA
48765225700121
(secondaire)
46.73ACréation
12/30/2006
Fermeture
2/28/2019
LA TUILIERE
83480 PUGET-SUR-ARGENS
CIFFREO BONA
48765225700220
(secondaire)
46.73BCréation
12/30/2006
Fermeture
3/25/2014
PANSARD
DOMAINE
83250 LA LONDE LES MAURES
CIFFREO BONA
48765225700154
(secondaire)
46.73ACréation
12/30/2006
Fermeture
4/30/2019
RTE NATIONALE 7
PONT DU BLAVET
83380 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
CIFFREO BONA - L'ENTREPOT DES PROS
48765225700170
(secondaire)
46.73ACréation
12/30/2006
Fermeture
1/31/2009
ZONE INDUSTRIELLE
83170 BRIGNOLES
48765225700014
(secondaire)
74.1JCréation
12/20/2005
Fermeture
6/30/2006
2 RUE DIDEROT
06000 NICE