SULO FRANCE
 
UNITÉ LÉGALE
Dénomination SocialeSULO FRANCE
Siège Social1 RUE DU DEBARCADERE
BATIMENT A IMMEUBLE PERSPECTIVE DEFENS
92700 COLOMBES
Forme JuridiqueSAS, société par actions simplifiée
Immatriculation1/1/1960
N° SIREN778151944
Capitalundefined undefined
Code NAF22.22Z (NAFRev2)
ActivitéFabrication d'emballages en matières plastiques
Effectif salarié500 à 999
TVA IntracommunautaireFR9778151944
Convention CollectiveIDCC 292 : Plasturgie
HISTORIQUE
11/1/2023Transfert de siège → 77815194401229
1/18/2019Transfert de siège → 77815194401120
1/18/2019Changement de dénomination sociale → SULO FRANCE
10/31/2016Changement de catégorie → économie non sociale
1/1/2008Changement d'activité → 22.22Z (NAFRev2)
5/24/2007Changement de forme → SAS, société par actions simplifiée
12/25/2004Changement d'activité → 25.2C (NAFRev1)
1/1/1997Changement de dénomination sociale → PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAINS
1/1/1989Changement de dénomination sociale → PLASTIC OMNIUM SA
1/1/1960Création → PLASTIC OMNIUM INDUSTRIE SA à conseil d'administration (s.a.i.)
OBSERVATIONS
08/08/1990 Fusion absorption par la société de la société PLASTIC OMNIUM S.A. siège social à LYON69007 19 Avenue Jules Carteret, RCS LYON B 683 620 157
15/03/1994 Fusion absorption de la société VILLES PROPRES - SA - RCS LYON B 317 883 205 - 19 avenue Jules Carteret 69007 LYON par la société PLASTIC OMNIUM - SA - RCS LYON B 778 151 944 - 19 avenue Jules Carteret 69007 LYON à compter du 30/12/1993 avec effect rétroactif au 01/01/1993
09/10/2007 NOTIFICATION INTERGREFFE DU TC DE LYON : CHGT DE FORME JURIDIQUE A CPTER DU 01/10/07 : SA A CONSEIL D ADMINISTRATION / NV : SAS
08/01/2015 Apport partiel d'actif de la branche autonome et complète d'activité "Services Supports et de Recherche et Développement pour la Division Environnement" appartenant à la société PLASTIC OMNIUM ENVIRONNEMENT SAS, 19 Avenue Jules Carteret 69007 LYON, 350 686 408 RCS GTC Lyon, suivant assemblée générale du 22/12/2014 avec effet au 31/12/2014.
22/12/2016 Fermeture d'un établissement secondaire sis 12 et 14 Avenue Tony Garnier 69007 LYON à compter du 31/10/2016
23/09/2020 Radiation du RCS le 23/09/2020 avec effet au 01/04/2014
17/12/2020 Radiation du RCS de Nancy le 17/12/2020 avec effet au 31/12/2020
20/01/2021 Radiation du RCS de Fréjus le 20/01/2021 avec effet au 18/01/2021
10/10/2023 Radiation du RCS de Montpellier le 02/10/2023
28/12/2023 Radiation du RCS de Cherbourg le 31/12/2023
12/12/2016 Observations concernant l'établissement situé 20 rue des Landelles 35510 Cesson-Sévigné : Observation depuis le 18/10/1991 : - ORIGINE DE L'ETABLISSEMENT : * DU 01.09.1991 AU 01.01.2004, RENNES, 130 RUE EUGENE POTTIER, CENTRE D'AFFAIRES LE CALYPSO, CREATION, TRANSFERE
12/12/2016 - Date de début d'activité : 25/02/1946.
16/10/2007 CODES STATISTIQUES ATTRIBUES PAR L'INSEE. APE : 252C Fabrication d'emballages en matières plastiques SIRET : 778 151 944 00759
08/10/2007 LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 67 031 600.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 10 218 901.54 EUR
26/05/2011 RCS LYON : 89 B 1130 -
REPRÉSENTANTS
typeDirecteur GénéralLatifa ZAHOUANI
né(e) en 10/1968
Nationalité Française
95150 Taverny
FRANCE
typeAutreMAZARS
61 Rue Henri Regnault
Tour Exaltis
92400 Courbevoie
BÉNÉFICIAIRES
typeL'Accès au registre des bénéficiaires effectifs est désormais réservé aux professions listées à l'article L.561-2 du CMF.
Si vous êtes avocat, notaire, huissier, comptable, journaliste, vous pouvez demander un accès via ce formulaire.
Si vous disposez déjà d'un code d'accès, veuillez le renseigner ici :
ACTES - (62 actes dans 43 dépôts)
pdf2akXW7ZuxRHQ C0022A1001L972310D20231129H181656TPIJTES003PDBOR
pdfExtrait de décision(s) de l'associé unique
Modification relative aux dirigeants d'une société de personnes
pdfExtrait de décision(s) de l'associé unique
Modification des statuts

Statuts mis à jour
Modification des statuts
pdfExtrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Modification relative aux dirigeants d'une société
pdfStatuts mis à jour
Modification des statuts

Procès-verbal d'assemblée générale
Modification des statuts
pdfProcès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des commissaires aux comptes

Statuts mis à jour
Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des commissaires aux comptes
pdfDécision(s) de l'associé unique
Modification de la dénomination de la personne morale Transfert siège social et établissement principal

Statuts mis à jour
Modification de la dénomination de la personne morale Transfert siège social et établissement principal
pdfDécision(s) de l'actionnaire unique
Modification relative aux dirigeants d'une société de personnes
pdfDécision(s) de l'actionnaire unique
Modification relative aux dirigeants d'une société de personnes
pdfExtrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte
Modification des statuts

Statuts mis à jour
Modification des statuts
pdfDéclaration de conformité
Décision sur la modification du capital social Modification de la durée de la personne morale Apport partiel d'actif placé sous le régime des fusions/scissions

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Décision sur la modification du capital social Modification de la durée de la personne morale Apport partiel d'actif placé sous le régime des fusions/scissions

Statuts mis à jour
Décision sur la modification du capital social Modification de la durée de la personne morale Apport partiel d'actif placé sous le régime des fusions/scissions
pdfRapport du commissaire aux apports
projet de scission
pdfProjet
Apport partiel d'actif placé sous le régime des fusions/scissions
pdfOrdonnance du président
Nomination de commissaire à la fusion
pdfProcès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Modification des commissaires aux comptes
pdfRapport du commissaire à la transformation
Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants d'une société

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants d'une société

Statuts mis à jour
Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants d'une société
pdfExtrait de procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Modification des statuts

Statuts mis à jour
Modification des statuts
pdfLettre de démission
Modification relative aux dirigeants d'une société

Procès-verbal du conseil d'administration
Modification relative aux dirigeants d'une société

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Modification relative aux dirigeants d'une société
pdfProcès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Mise en harmonie des statuts

Statuts mis à jour
Mise en harmonie des statuts
pdfProcès-verbal du conseil d'administration
Modification relative aux dirigeants d'une société
pdfProcès-verbal du conseil d'administration
Décision sur la modification du capital social Modification relative aux dirigeants d'une société

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Décision sur la modification du capital social Modification relative aux dirigeants d'une société

Statuts mis à jour
Décision sur la modification du capital social Modification relative aux dirigeants d'une société
pdfProcès-verbal du conseil d'administration
Modification relative aux dirigeants d'une société
pdfActe
Modification des dirigeants, organes de contrôle
pdfActe
Modification des dirigeants, organes de contrôle
pdfActe
Modification des dirigeants, organes de contrôle
pdfActe
Modification des dirigeants, organes de contrôle
pdfActe
Modification des dirigeants, organes de contrôle
pdfOrdonnance du président
Nomination de commissaire aux apports
pdfDéclaration de conformité
Apport partiel d'actif Modification dénomination - objet social

Acte
Apport partiel d'actif Modification dénomination - objet social

Statuts mis à jour
Apport partiel d'actif Modification dénomination - objet social
pdfActe
Modification des dirigeants, organes de contrôle
pdfActe
Apport partiel d'actif
pdfOrdonnance du président
pdfOrdonnance du président
Nomination de commissaire aux apports
pdfActe
Modification des dirigeants, organes de contrôle
pdfActe
Apport partiel d'actif
pdfOrdonnance du président
Nomination de commissaire à la scission
pdfOrdonnance du président
Nomination de commissaire à la scission
pdfOrdonnance du président
Nomination de commissaire aux apports
pdfActe
Modification des dirigeants, organes de contrôle
pdf2JuW1NaltwqG RACT9400180898
pdfRapport du commissaire aux apports
Apport fusion
pdfActe
fusion absorption

Projet
fusion absorption
pdfActe
Modification des dirigeants, organes de contrôle
pdfOrdonnance du président
COMPTES
Clôture
31/12/2023
Dépôt
08/07/2024
Clôture
31/12/2022
Dépôt
18/08/2023
Clôture
31/12/2021
Dépôt
19/07/2022
Clôture
31/12/2020
Dépôt
25/08/2021
Clôture
31/12/2019
Dépôt
29/07/2020
Clôture
31/12/2018
Dépôt
05/09/2019
Clôture
31/12/2017
Dépôt
12/07/2018
Clôture
31/12/2016
Dépôt
13/06/2017
BODACC
7/10/2024NANTERREDépôts des comptes
11/28/2023NANTERREModifications diverses
8/24/2023LYONDépôts des comptes
7/13/2023LYONModifications diverses
7/28/2022LYONDépôts des comptes
9/1/2022LYONModifications diverses
9/2/2021LYONDépôts des comptes
8/16/2020LYONDépôts des comptes
10/3/2019LYONDépôts des comptes
8/8/2019LYONModifications diverses
2/21/2019LYONModifications diverses
3/8/2018LYONModifications diverses
12/23/2018LYONModifications diverses
8/9/2018LYONDépôts des comptes
6/28/2017LYONDépôts des comptes
8/3/2016LYONDépôts des comptes
6/22/2015LYONDépôts des comptes
1/23/2015LYONModifications diverses
12/16/2015LYONVentes et cessions
6/14/2014LYONDépôts des comptes
11/20/2014LYONVentes et cessions
5/25/2014ÉVRYVentes et cessions
8/20/2013LYONDépôts des comptes
8/1/2012LYONDépôts des comptes
9/8/2011LYONDépôts des comptes
9/16/2010LYONDépôts des comptes
8/26/2010LYONModifications diverses
8/8/2009LYONDépôts des comptes
7/26/2009LYONModifications diverses
8/29/2008LYONDépôts des comptes
1/27/2008LYONModifications diverses
ETABLISSEMENTS
SULO FRANCE SIEGE
77815194401229
(siège)
22.22ZCréation
8/26/2019
 1 RUE DU DEBARCADERE
BATIMENT A IMMEUBLE PERSPECTIVE DEFENS
92700 COLOMBES
77815194401468
(secondaire)
22.22ZCréation
2/1/2025
 RUE DES CEDRES
45260 LORRIS
77815194401450
(secondaire)
22.22ZCréation
10/28/2024
 12 RUE DES LONGUES RAIES
78440 GARGENVILLE
77815194401443
(secondaire)
22.22ZCréation
10/1/2024
 47 ALLEE DES DEUX POTEAUX
33127 SAINT JEAN D ILLAC
77815194401419
(secondaire)
22.22ZCréation
7/19/2007
 60 CHEMIN DE FONT GRAISSAN
06250 MOUGINS
77815194401401
(secondaire)
22.22ZCréation
4/1/2024
 608 AVENUE SAINT MAUR
83310 COGOLIN
77815194401435
(secondaire)
22.22ZCréation
2/14/2024
 209 AVENUE DE LA REPUBLIQUE
ET 21 RUE DE L'YSER
93800 EPINAY-SUR-SEINE
77815194401336
(secondaire)
22.22ZCréation
10/1/2022
 95 RUE DE LA MUSSE
37530 CHARGE
77815194401310
(secondaire)
22.22ZCréation
7/1/2021
 9073 RUE DU MOULIN A VENT
PLAINE DU MOULIN A VENT
76760 YERVILLE
77815194401286
(secondaire)
22.22ZCréation
1/15/2020
 298 AVENUE DE LA LIBERTE
86180 BUXEROLLES
77815194401260
(secondaire)
46.69BCréation
12/31/2019
 16 AVENUE DU QUEBEC
ENTREE NUMERO 2
91140 VILLEBON-SUR-YVETTE
77815194401252
(secondaire)
22.22ZCréation
12/31/2019
 240 RUE LOUIS DE BROGLIE
PARC DE LA DURANNE
13290 AIX-EN-PROVENCE
SULO FRANCE RCF
77815194401237
(secondaire)
22.22ZCréation
8/26/2019
 1 RUE DU DEBARCADERE
ETAGE 6 RESEAUX
92700 COLOMBES
77815194401245
(secondaire)
22.22ZCréation
7/1/2019
 556 CHEMIN DU MAS DE CHEYLON
30900 NIMES
77815194401211
(secondaire)
22.22ZCréation
4/1/2013
 84 RUE EDOUARD BELIN
ZI MARCEROLLES
26500 BOURG-LES-VALENCE
77815194401195
(secondaire)
22.22ZCréation
1/1/2018
 PARC D’ACTIVITE DE L’ARGILE
LOT 43
06370 MOUANS-SARTOUX
77815194401187
(secondaire)
22.22ZCréation
11/1/2017
 RUE BECQUEREL
ARTISANALE CORNE NEUVE
17139 DOMPIERRE-SUR-MER
77815194401153
(secondaire)
70.10ZCréation
10/24/2016
 3 RUE GARIBALDI
DIRECTION DE LA RECHERCHE ET DEVELOPPE
69800 SAINT-PRIEST
77815194401120
(secondaire)
22.22ZCréation
7/1/2016
 3 RUE GARIBALDI
69800 SAINT-PRIEST
77815194401138
(secondaire)
22.22ZCréation
7/1/2016
 ZONE ARTISANALE LA MORANDIERE
35220 SAINT-JEAN-SUR-VILAINE
77815194401146
(secondaire)
22.22ZCréation
7/1/2016
 3 RUE GARIBALDI
DIRECTION REGIONALE CENTRE EST
69800 SAINT-PRIEST
77815194401104
(secondaire)
22.22ZCréation
7/1/2015
 242 IMP DES 2 POTEAUX
33127 SAINT JEAN D'ILLAC
77815194401070
(secondaire)
22.22ZCréation
7/1/2014
 RUE FRITZ LAUER
ZA LANNOLIER
11000 CARCASSONNE
77815194401054
(secondaire)
22.22ZCréation
10/1/2013
 77 RUE ALBERT GARRY
94450 LIMEIL-BREVANNES
77815194401047
(secondaire)
22.22ZCréation
6/1/2013
 492 BOULEVARD DU MERCANTOUR
06200 NICE
77815194400940
(secondaire)
22.22ZCréation
4/1/2010
 17 CHEMIN DES PIERRES
31150 BRUGUIERES
77815194400841
(secondaire)
22.22ZCréation
1/1/2007
 523 CHE ROBERT BRUN
83500 LA SEYNE SUR MER
77815194400858
(secondaire)
22.22ZCréation
2/1/2006
 20 RUE DENIS PAPIN
51100 REIMS
77815194400833
(secondaire)
22.22ZCréation
1/15/2006
 218 RUE DE LA LOUVIERE
59273 FRETIN
77815194400767
(secondaire)
22.22ZCréation
4/1/2004
 5 ZI LES TEPPES
73460 FRONTENEX
77815194400734
(secondaire)
22.22ZCréation
9/1/2003
 9 ROUTE DES CHAMPS FOURGONS
7
92230 GENNEVILLIERS
AGENCE COMMERCIALE
77815194400627
(secondaire)
22.22ZCréation
9/1/1999
 ZI NOUVELLES FRANCHISES
52200 LANGRES
77815194400619
(secondaire)
22.22ZCréation
7/1/1999
 RUE CHARLES RICHET
34500 BEZIERS
77815194400486
(secondaire)
22.22ZCréation
9/1/1997
 RUE DENIS PAPIN
ZONE PORTUAIRE NORD
71100 CHALON-SUR-SAONE
77815194400080
(secondaire)
22.22ZCréation
12/18/1989
 LE RUISSEAU PERDU
19110 BORT LES ORGUES
77815194400189
(secondaire)
22.22ZCréation
12/18/1989
 RUE DE L’ETOILE DE LANGRES
ZI-FAUBOURG DES FRANCHISES
52200 LANGRES
77815194400288
(secondaire)
22.22ZCréation
7/1/1985
 19 RUE NEWTON
ZI DU BREZET
63100 CLERMONT-FERRAND
77815194401427
(secondaire)
22.22ZCréation
8/26/2024
Fermeture
1/22/2025
37 AVENUE DE LA PROSPECTIVE
18000 BOURGES
77815194401393
(secondaire)
22.22ZCréation
3/25/2024
Fermeture
11/15/2024
35 RUE DE LIHONS
80170 ROSIERES-EN-SANTERRE
77815194401385
(secondaire)
22.22ZCréation
12/20/2023
Fermeture
11/15/2024
685 RUE JEAN PERRIN
59500 DOUAI
77815194401377
(secondaire)
22.22ZCréation
10/31/2023
Fermeture
10/31/2023
3 RUE GARIBALDI
BATIMENT A IMMEUBLE PERSPECTIVE DEFENS
69800 SAINT-PRIEST
77815194401344
(secondaire)
22.22ZCréation
11/8/2022
Fermeture
1/12/2024
2 B RUE DE CANNES
59000 LILLE
77815194401369
(secondaire)
22.22ZCréation
9/1/2022
Fermeture
12/31/2023
2 RUE DE BRETAGNE
38130 ECHIROLLES
77815194401351
(secondaire)
22.22ZCréation
9/1/2022
Fermeture
10/1/2023
44 RUE DES MANUFACTURIERS
42640 SAINT-ROMAIN-LA-MOTTE
77815194401328
(secondaire)
22.22ZCréation
8/16/2021
Fermeture
10/2/2023
286 RUE CHARLES GIDE
34670 BAILLARGUES
77815194401294
(secondaire)
46.69BCréation
12/31/2019
Fermeture
12/31/2020
420 A RUE DE L'ESCADRILLE DES CIGOGNES
54200 TOUL
77815194401278
(secondaire)
46.69BCréation
12/31/2019
Fermeture
11/1/2023
165 RUE DES FOUGERES
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN
77815194401203
(secondaire)
22.22ZCréation
9/20/2018
Fermeture
1/1/2022
B AVENUE DE MEYRARGUES
34740 VENDARGUES
77815194401179
(secondaire)
22.22ZCréation
11/13/2017
Fermeture
1/1/2021
22 AVENUE DE LA BALTIQUE
PARC DE HIGHTEC 2
91140 VILLEBON-SUR-YVETTE
77815194401161
(secondaire)
22.22ZCréation
5/1/2017
Fermeture
8/31/2020
4 RUE PIERRE DE MAUPERTUIS
CAMPUS KER LANN - BATIMENT B
35170 BRUZ
77815194401112
(secondaire)
22.22ZCréation
12/1/2015
Fermeture
10/31/2017
B RUE DU PEUX BAUDIN
17630 LA FLOTTE
77815194401096
(secondaire)
22.22ZCréation
1/1/2015
Fermeture
12/31/2016
AVENUE DU BOIS DES VERGNES
01150 SAINTE-JULIE
77815194401088
(secondaire)
22.22ZCréation
5/1/2014
Fermeture
1/18/2021
RUE CONDORCET
ZA
83310 COGOLIN
77815194401302
(secondaire)
22.22ZCréation
4/1/2014
Fermeture
4/1/2014
LE CAPISCOL
ZI
34500 BEZIERS
77815194401062
(secondaire)
22.22ZCréation
2/5/2014
Fermeture
6/30/2016
4 IMPASSE MAURICE LEVY
33700 MERIGNAC
77815194401021
(secondaire)
22.22ZCréation
2/1/2013
Fermeture
12/31/2015
LA GRANDE BOURRELIERE
45510 NEUVY-EN-SULLIAS
77815194401039
(secondaire)
22.22ZCréation
2/1/2013
Fermeture
9/1/2017
RUE LOUISE LABE
ZAC DE CHAPOTIN
69970 CHAPONNAY
77815194400999
(secondaire)
22.22ZCréation
11/1/2012
Fermeture
12/31/2020
63 RUE EDOUARD COLONNE
92000 NANTERRE
77815194401005
(secondaire)
22.22ZCréation
9/1/2012
Fermeture
6/30/2014
6 RUE CHARLES AUGUSTIN COULOMB
ZA DE L'ARNOUZETTE
11000 CARCASSONNE
77815194401013
(secondaire)
22.22ZCréation
7/1/2012
Fermeture
6/30/2015
RUE THOMAS EDISON
ANGLE DE LA RUE GASPARD MONGE
33610 CANEJAN
77815194400981
(secondaire)
22.22ZCréation
5/1/2012
Fermeture
3/31/2020
53 RUE LOUIS PROUST
ZONE INDUSTRIELLE SAINT CEZAIRE
30900 NIMES
77815194400973
(secondaire)
22.22ZCréation
1/1/2012
Fermeture
12/31/2014
24 RUE DES CITES DU CANAL
ZI DU CANAL
54250 CHAMPIGNEULLES
77815194400965
(secondaire)
22.22ZCréation
10/1/2011
Fermeture
12/1/2016
5 IMP DES TILLEULS
90800 ARGIESANS
77815194400957
(secondaire)
22.22ZCréation
7/1/2011
Fermeture
5/31/2018
LE CLOS DE VILLIERS
ZONE ARTISANALE
49250 LES BOIS D'ANJOU
77815194400932
(secondaire)
22.22ZCréation
1/27/2011
Fermeture
12/31/2016
4 IMPASSE DU MARRAUD
10600 BARBEREY-SAINT-SULPICE
77815194400924
(secondaire)
22.22ZCréation
5/1/2010
Fermeture
10/31/2016
12 AVENUE TONY GARNIER
12-14
69007 LYON
77815194400908
(secondaire)
22.22ZCréation
7/1/2009
Fermeture
9/30/2021
8 RUE NARCISSE GUILBERT
76570 PAVILLY
77815194400874
(secondaire)
22.22ZCréation
11/30/2008
Fermeture
12/31/2020
1 ALLEE PIERRE BURELLE
2 EME ETAGE
92300 LEVALLOIS-PERRET
77815194400890
(secondaire)
22.22ZCréation
10/1/2008
Fermeture
9/30/2011
LE PETIT RONCERAY
49430 DURTAL
77815194400882
(secondaire)
22.22ZCréation
9/1/2008
Fermeture
8/31/2011
59 IMPASSE AMPERE
ZONE ACTI SUD
85000 LA ROCHE-SUR-YON
77815194400916
(secondaire)
22.22ZCréation
4/23/2008
Fermeture
8/1/2009
9 RUE DU MOULIN A POUDRE
76150 MAROMME
77815194400866
(secondaire)
25.2CCréation
7/3/2006
Fermeture
7/3/2006
20 RUE DES LANDELLES
REZ DE CHAUSSEE
35510 CESSON-SEVIGNE
77815194400825
(secondaire)
22.22ZCréation
1/31/2006
Fermeture
12/31/2022
CHE DES GROSSES PIERRES
ZI DE LA BOISTARDIERE
37530 CHARGE
77815194400809
(secondaire)
22.22ZCréation
1/1/2006
Fermeture
11/30/2008
63 RUE EDOUARD COLONNE
2 ETAGE
92000 NANTERRE
77815194400817
(secondaire)
46.69BCréation
11/1/2005
Fermeture
10/30/2011
77 RUE DE BEAUFORT
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT
77815194400791
(secondaire)
22.22ZCréation
6/1/2005
Fermeture
1/27/2011
42 RUE JEAN-BAPTISTE COLBERT
10600 LA CHAPELLE-SAINT-LUC
77815194400783
(secondaire)
22.22ZCréation
3/1/2005
Fermeture
1/1/2008
20 RUE DES 2 PONTS
18230 SAINT-DOULCHARD
77815194400775
(secondaire)
22.22ZCréation
2/1/2005
Fermeture
9/30/2011
RUE D'ITALIE
ZI HEIDEN OUEST
68310 WITTELSHEIM
77815194400759
(secondaire)
22.22ZCréation
4/1/2004
Fermeture
4/1/2019
99 AVENUE DE LYON
LE GEAI
26500 BOURG-LES-VALENCE
77815194400742
(secondaire)
22.22ZCréation
1/1/2004
Fermeture
10/31/2016
20 RUE DES LANDELLES
35510 CESSON-SEVIGNE
77815194400726
(secondaire)
22.22ZCréation
5/1/2003
Fermeture
5/1/2012
18 AVENUE DE GENESTET
30320 MARGUERITTES
77815194400700
(secondaire)
25.2CCréation
1/1/2002
Fermeture
9/30/2003
211 CHEMIN PRE GUILLERME
38660 LUMBIN
77815194400718
(secondaire)
22.22ZCréation
1/1/2002
Fermeture
5/30/2013
169 CHEMIN DES CARDELINES
06370 MOUANS-SARTOUX
77815194400684
(secondaire)
22.22ZCréation
6/1/2001
Fermeture
10/1/2012
38 RUE DU BOURGAMON
38400 SAINT-MARTIN-D'HERES
77815194400676
(secondaire)
22.22ZCréation
4/1/2001
Fermeture
4/1/2010
328 AVENUE DE FRONTON
31200 TOULOUSE
77815194400692
(secondaire)
25.2CCréation
3/1/2001
Fermeture
5/31/2005
RUE DU CONTRE HALAGE
ZA DU VAL D'YONNE
89100 PARON
77815194400650
(secondaire)
22.22ZCréation
2/1/2001
Fermeture
11/30/2008
59 RUE EDOUARD COLONNE
59 A 63
92000 NANTERRE
77815194400643
(secondaire)
25.2CCréation
1/1/2001
Fermeture
1/1/2007
RUE LAVOISIER
83210 LA FARLEDE
77815194400635
(secondaire)
22.22ZCréation
11/1/2000
Fermeture
4/15/2021
28 ROUTE DE DEMIGNY
71530 CHAMPFORGEUIL
77815194400593
(secondaire)
25.2CCréation
1/28/1999
Fermeture
4/1/2001
8 AVENUE D'HERMES
ZA DE MONTREDON
31240 L'UNION
77815194400668
(secondaire)
25.2CCréation
1/1/1999
Fermeture
12/31/2003
77 AV VIEUX CHEMIN ST DENIS
92230 GENNEVILLIERS
77815194400569
(secondaire)
25.2CCréation
10/1/1998
Fermeture
12/31/2001
724 BOULEVARD DU MERCANTOUR
06200 NICE
77815194400528
(secondaire)
22.22ZCréation
2/1/1998
Fermeture
11/1/2023
15 RUE VICTOR GRIGNARD
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN
77815194400551
(secondaire)
22.22ZCréation
1/1/1998
Fermeture
7/1/2014
RUE CHARLES AUGUSTIN COULOMB
ZA DE L'ARNOUZETTE
11000 CARCASSONNE
77815194400536
(secondaire)
25.2CCréation
1/1/1998
Fermeture
1/1/2001
100 AVENUE DU 14 JUILLET 1789
83130 LA GARDE
77815194400494
(secondaire)
25.2CCréation
10/1/1997
Fermeture
6/30/2006
RUE DU TY MOR
ZI
56700 HENNEBONT
77815194400502
(secondaire)
22.22ZCréation
9/1/1997
Fermeture
12/31/2011
16 RUE LEO VALENTIN
88000 EPINAL
77815194400585
(secondaire)
22.22ZCréation
8/1/1997
Fermeture
1/31/2014
12 RUE CLAUDE CHAPPE
ZA MAGELLAN
33600 PESSAC
77815194400460
(secondaire)
51.6GCréation
5/12/1997
Fermeture
2/1/1998
38 B RUE GRANDE VALLEE
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN
77815194400452
(secondaire)
22.22ZCréation
5/2/1997
Fermeture
10/31/2008
117 BOULEVARD DE L'INDUSTRIE
85000 LA ROCHE-SUR-YON
77815194400445
(secondaire)
25.2CCréation
4/28/1997
Fermeture
11/1/2005
4 ALL GUSTAVE EIFFEL
87410 LE PALAIS SUR VIENNE
77815194400601
(secondaire)
22.22ZCréation
4/1/1997
Fermeture
4/23/2008
35 QUAI GUSTAVE FLAUBERT
76380 CANTELEU
77815194400577
(secondaire)
25.2CCréation
1/1/1997
Fermeture
12/31/2001
54 RUE DU COLONEL ROZANOFF
89660 CHATEL-CENSOIR
77815194400544
(secondaire)
25.2HCréation
1/1/1997
Fermeture
12/25/1997
LE RUE D'AUSSOR
89660 CHATEL-CENSOIR
77815194400510
(secondaire)
25.2HCréation
1/1/1996
Fermeture
9/15/1997
23 RUE ANDRE FRUCHARD
54320 MAXEVILLE
77815194400478
(secondaire)
22.22ZCréation
5/1/1995
Fermeture
10/1/2013
32 RUE ROBERT WITCHITZ
ET 34
94200 IVRY-SUR-SEINE
77815194400429
(secondaire)
22.22ZCréation
1/1/1995
Fermeture
12/31/2012
33 AVENUE DE LA LIBERATION
65000 TARBES
SE3
77815194400437
(secondaire)
25.2CCréation
1/1/1995
Fermeture
12/31/1998
40 RUE PAUL VAILLANT-COUTURIER
040-042BIS
92300 LEVALLOIS-PERRET
77815194400411
(secondaire)
25.2CCréation
12/15/1994
Fermeture
1/1/2002
114 AVENUE LOUIS ROCHE
92230 GENNEVILLIERS
77815194400403
(secondaire)
25.2CCréation
9/1/1994
Fermeture
1/15/2006
19 RUE DE LA VOYETTE
CENTRE DE GROS
59273 FRETIN
77815194400395
(secondaire)
25.2HCréation
2/1/1994
Fermeture
12/25/1996
12 RUE MOLIERE
94200 IVRY-SUR-SEINE
77815194400387
(secondaire)
74.7ZCréation
1/1/1994
Fermeture
12/25/1994
97 RUE DU MOULIN DE CAGE
92230 GENNEVILLIERS
77815194400361
(secondaire)
25.2HCréation
7/21/1992
Fermeture
9/1/1997
LES GRANDES LANDES
35580 GUICHEN
77815194400379
(secondaire)
74.8KCréation
1/15/1992
Fermeture
12/31/1997
32 RUE DES MOREAUX
89000 AUXERRE
77815194400312
(secondaire)
25.2CCréation
9/20/1991
Fermeture
6/1/2001
73 RUE DES JAVAUX
ZI DES JAVAUX
38320 EYBENS
77815194400304
(secondaire)
22.22ZCréation
9/19/1991
Fermeture
1/31/2016
4 RUE DU CDT L'HERMINIER
79000 NIORT
77815194400338
(secondaire)
25.2CCréation
9/1/1991
Fermeture
1/1/2004
130 RUE EUGENE POTTIER
IMMEUBLE LE CALYPSO
35000 RENNES
77815194400247
(secondaire)
25.2CCréation
6/20/1991
Fermeture
12/25/1999
156 AVENUE JEAN JAURES
33600 PESSAC
77815194400254
(secondaire)
25.2CCréation
4/1/1991
Fermeture
1/31/2006
CHEMIN DES PENDANTS
51450 BETHENY
77815194400221
(secondaire)
25.2HCréation
1/1/1990
Fermeture
9/1/1997
LD LA CROIX LETERQUE
76430 SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC
77815194400213
(secondaire)
74.1JCréation
1/1/1990
Fermeture
7/30/1992
BOULEVARD DE LA HAIE DES COGNETS
35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
77815194400130
(secondaire)
25.2HCréation
12/18/1989
Fermeture
1/1/1998
37 RUE AMBROISE PARE
QUARTIER BRUNET
83100 TOULON
77815194400163
(secondaire)
22.22ZCréation
12/18/1989
Fermeture
12/31/2020
1 ALLEE PIERRE BURELLE
1-3
92300 LEVALLOIS-PERRET
77815194400106
(secondaire)
25.2CCréation
12/18/1989
Fermeture
7/31/2005
520 AVENUE DES PRES D'ARENES
34070 MONTPELLIER
77815194400353
(secondaire)
25.2HCréation
12/18/1989
Fermeture
9/1/1997
20 AVENUE DE LA GARE
38290 LA VERPILLIERE
77815194400114
(secondaire)
74.1JCréation
12/18/1989
Fermeture
6/30/1994
79 RUE DU DOCTEUR LEGAY
59110 LA MADELEINE
77815194400205
(secondaire)
25.2HCréation
12/18/1989
Fermeture
1/28/1999
42 CHEMIN DES RAMIERS
31700 BLAGNAC
77815194400171
(secondaire)
25.2HCréation
12/18/1989
Fermeture
12/31/1997
ZI DANJOUTIN
90400 DANJOUTIN
77815194400072
(secondaire)
25.2HCréation
12/18/1989
Fermeture
9/1/1997
501 RUE ALFRED LEROY
62700 BRUAY-LA-BUISSIERE
77815194400098
(secondaire)
25.2HCréation
12/18/1989
Fermeture
9/1/1997
RAVIN D OLIMA
88000 CHANTRAINE
77815194400122
(secondaire)
25.2HCréation
12/18/1989
Fermeture
12/31/1998
ROUTE DE LA BARONNE
HAMEAU DE LA BARONNE
06610 LA GAUDE
77815194400239
(secondaire)
25.2CCréation
1/24/1989
Fermeture
12/31/2003
10 AVENUE EMMANUEL ALLARD
13011 MARSEILLE
77815194400296
(secondaire)
25.2HCréation
1/1/1989
Fermeture
12/31/1994
ZI DES ANSEREUILLES ALL B
PARC ACTIVITE DES ANSEREUI
59136 WAVRIN
77815194400064
(secondaire)
22.22ZCréation
12/22/1988
Fermeture
1/18/2019
19 BOULEVARD JULES CARTERET
69007 LYON
77815194400270
(secondaire)
25.2CCréation
1/1/1988
Fermeture
1/30/2006
CHEMIN DU ROI
ZI DE LA BOISTARDIERE
37400 AMBOISE
77815194400031
(secondaire)
25.2HCréation
12/31/1986
Fermeture
9/1/1997
RUE DE LA CROIX DE PIERRE
LONGPRE LES AMIENS
80080 AMIENS
77815194400056
(secondaire)
25.2HCréation
12/31/1986
Fermeture
1/1/1997
37 AVENUE DE L'EUROPE
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
77815194400023
(secondaire)
25.2HCréation
12/31/1986
Fermeture
9/1/1997
ZI
39360 VIRY
77815194400346
(secondaire)
25.2CCréation
9/1/1985
Fermeture
4/1/2004
9 CHEMIN DU COLOMBIER
26000 VALENCE
77815194400320
(secondaire)
25.2HCréation
6/1/1983
Fermeture
12/31/1997
QUAI DU DANEMARK
76380 CANTELEU
77815194400262
(secondaire)
25.2HCréation
9/1/1981
Fermeture
10/1/1997
ZA DE KERMASONETTE
56700 KERVIGNAC
77815194400015
(secondaire)
25.2HCréation
1/1/1900
Fermeture
12/25/1997
85 RUE CASTELLION
01100 OYONNAX
MARQUES
BREVETS
FR 3015916INSTALLATION POUR LA DECOUPE EN TRANCHES D'UNE DENREE ALIMENTAIRE ALLONGEE, EN PARTICULIER UN MEMBRE D'ANIMAL12/26/20131/1/2019
FR 2835511CONDITIONNEMENT DE PORTIONS INDIVIDUELLES DE PRODUITS CRUS OU CUITS, EMBALLAGES SOUS VIDE ET/OU ATMOSPHERE CONTROLEE2/5/2002
FR 3011717PROCEDE ET INSTALLATION POUR L'OBTENTION DE PIECES DE VIANDE QUI PRESENTENT DES FORMES ET DES POIDS CIBLES HOMOGENES10/14/201310/30/2017
FR 3028792INSTALLATION POUR LA DECOUPE EN MORCEAUX DE DENREES ALIMENTAIRES ALLONGEES, EN PARTICULIER DE PIECES DE VIANDE OU DE POISSON11/25/201411/29/2017
FR 2977185PROCEDE ET INSTALLATION POUR LA COUPE EN TRANCHES D'UNE DENREE ALIMENTAIRE, ET POUR L'INDIVIDUALISATION DES TRANCHES OBTENUES6/27/2011
FR 2972101PROCEDE POUR LE BRIDAGE D'UNE VOLAILLE ET INSTALLATION POUR LA MISE EN OEUVRE DU PROCEDE2/28/20114/2/2018
EP 2540462Procédé et installation pour la coupe en tranches d'une denrée alimentaire, et pour l'individualisation des tranches obtenues6/25/20127/1/2018
DESSINS ET MODÈLES